Elenchi del registro nazionale dei luoghi storici a Barnstable, Massachusetts - National Register of Historic Places listings in Barnstable, Massachusetts

Barnstable MA highlight large.png

Barnstable, Massachusetts , ha più di 75 voci nel registro nazionale dei luoghi storici . Per elenchi altrove nella contea di Barnstable , vedere gli elenchi del registro nazionale dei luoghi storici nella contea di Barnstable, Massachusetts .

Contenuto: contee del Massachusetts
Questo elenco del National Park Service è completo tramite i recenti elenchi NPS pubblicati il ​​7 maggio 2021.


Mappa tutte le coordinate usando: OpenStreetMap  
Scarica le coordinate come: KML

Elenchi attuali

Nome sul registro Immagine Data elencata Posizione Città o paese Descrizione
1 Adams-Crocker-Fish House
Adams-Crocker-Fish House
13 marzo 1987
( # 87000219 )
449 Willow St.
41 ° 42′07 ″ N 70 ° 23′22 ″ O  /  41.701944 ° N 70.389444 ° O  / 41.701944; -70.389444  ( Adams-Crocker-Fish House )
Barnstable
2 Casa di Josiah A. Ames
Casa di Josiah A. Ames
18 settembre 1987
( # 87000300 )
145 Bridge St.
41 ° 37′20 ″ N 70 ° 23′46 ″ O  /  41.622222 ° N 70.396111 ° O  / 41.622222; -70.396111  (Casa di Josiah A. Ames )
Barnstable
3 Antico terreno di sepoltura
Antico terreno di sepoltura
13 marzo 1987
( # 87000283 )
Phinney's Ln.
41 ° 39′17 "N 70 ° 20′38" O  /  41.6547 ° N 70.3439 ° O  / 41.6547; -70.3439  ( Antico terreno di sepoltura )
Barnstable
4 Benjamin Baker Jr. House
Benjamin Baker Jr. House
10 novembre 1987
( # 87000352 )
1579 Hyannis Rd.
41 ° 41′42 "N 70 ° 18′12" O  /  41,695 ° N 70,303333 ° O  / 41.695; -70.303333  (Casa di Benjamin Baker Jr. )
Barnstable
5 Capt. Seth Baker Jr. House
Capt. Seth Baker Jr. House
18 settembre 1987
( # 87000299 )
35 Main St.
41 ° 39′22 ″ N 70 ° 16′22 ″ O  /  41.656111 ° N 70.272778 ° O  / 41.656111; -70.272778  ( Capt. Seth Baker Jr. House )
Barnstable
6 Nathaniel Baker House
Nathaniel Baker House
13 marzo 1987
( # 87000229 )
1606 Hyannis Rd.
41 ° 41′45 "N 70 ° 18′08" O  /  41.695833 ° N 70.302222 ° O  / 41.695833; -70.302222  ( Nathaniel Baker House )
Barnstable
7 Tribunale della contea di Barnstable
Tribunale della contea di Barnstable
11 giugno 1981
( # 81000104 )
Strada principale
41 ° 42′05 ″ N 70 ° 18′17 ″ O  /  41.701389 ° N 70.304722 ° O  / 41.701389; -70.304722  ( Tribunale della contea di Barnstable )
Barnstable
8 Il capitano Rodney J. Baxter House
Il capitano Rodney J. Baxter House
13 marzo 1987
( # 87000273 )
South and Pearl Sts.
41 ° 39′00 "N 70 ° 17′06" O  /  41,65 ° N 70,285 ° O  / 41.65; -70.285  ( Capt. Rodney J. Baxter House )
Barnstable
9 Capt. Sylvester Baxter House
Capt. Sylvester Baxter House
13 marzo 1987
( # 87000313 )
156 Main Street
41 ° 39′19 ″ N 70 ° 16′39 ″ O  /  41.655278 ° N 70.2775 ° O  / 41.655278; -70.2775  ( Capt. Sylvester Baxter House )
Barnstable
10 Charles L. Baxter House
Charles L. Baxter House
13 marzo 1987
( # 87000315 )
77 Main St.
41 ° 38′08 ″ N 70 ° 27′02 ″ O  /  41.635556 ° N 70.450556 ° O  / 41.635556; -70.450556  (Casa di Charles L. Baxter )
Barnstable
11 Shubael Baxter House
Shubael Baxter House
18 settembre 1987
( # 87000304 )
9 E. Bay Rd.
41 ° 37′39 "N 70 ° 22′49" O  /  41.6275 ° N 70.380278 ° O  / 41.6275; -70.380278  ( Casa Shubael Baxter )
Barnstable
12 Capt. Allen H. Bearse House
Capt. Allen H. Bearse House
13 marzo 1987
( # 87000264 )
48 Camp St.
41 ° 39′25 ″ N 70 ° 16′33 ″ O  /  41.656944 ° N 70.275833 ° O  / 41.656944; -70.275833  ( Capt. Allen H. Bearse House )
Barnstable
13 Capt. Oliver Bearse House
Capt. Oliver Bearse House
13 marzo 1987
( # 87000276 )
39 Pearl St.
41 ° 39′03 ″ N 70 ° 17′07 ″ O  /  41.650833 ° N 70.285278 ° O  / 41.650833; -70.285278  ( Capt. Oliver Bearse House )
Barnstable Danneggiata da un incendio nel 2011 e successivamente demolita.
14 Casa Blish-Garret
Casa Blish-Garret
13 marzo 1987
( # 87000327 )
350 Plum St.
41 ° 41′41 ″ N 70 ° 21′21 ″ O  /  41.694722 ° N 70.355833 ° O  / 41.694722; -70.355833  (Casa Blish-Garret )
Barnstable
15 Edificio al 237–239 Main Street
Edificio al 237–239 Main Street
13 marzo 1987
( # 87000293 )
237–239 Main Street
41 ° 39′16 ″ N 70 ° 16′49 ″ O  /  41.654444 ° N 70.280278 ° O  / 41.654444; -70.280278  ( Edificio a 237–239 Main Street )
Barnstable
16 Edificio a 600 Main Street
Edificio a 600 Main Street
13 marzo 1987
( # 87000286 )
600 Main Street
41 ° 38′56 ″ N 70 ° 17′28 ″ O  /  41.648889 ° N 70.291111 ° O  / 41.648889; -70.291111  ( Edificio a 600 Main Street )
Barnstable
17 Edificio al 606 Main Street
Edificio al 606 Main Street
13 marzo 1987
( # 87000287 )
606 Main St.
41 ° 38′56 ″ N 70 ° 17′28 ″ O  /  41.648889 ° N 70.291111 ° O  / 41.648889; -70.291111  ( Edificio al 606 Main Street )
Barnstable
18 Edificio in 614 Main Street
Edificio in 614 Main Street
13 marzo 1987
( # 87000285 )
614 Main St.
41 ° 38′56 ″ N 70 ° 17′28 ″ O  /  41.648889 ° N 70.291111 ° O  / 41.648889; -70.291111  ( Edificio in 614 Main Street )
Barnstable
19 Collen C. Campbell House
Collen C. Campbell House
13 marzo 1987
( # 87000297 )
599 Main Street
41 ° 38′55 ″ N 70 ° 17′27 ″ O  /  41.648611 ° N 70.290833 ° O  / 41.648611; -70.290833  (Casa di Collen C. Campbell )
Barnstable
20 Casa Canary-Hartnett
Casa Canary-Hartnett
13 marzo 1987
( # 87000260 )
113 Winter St.
41 ° 39′10 ″ N 70 ° 17′14 ″ O  /  41.652778 ° N 70.287222 ° O  / 41.652778; -70.287222  (Casa Canary-Hartnett )
Barnstable
21 Quartiere storico di Centreville
Quartiere storico di Centreville
10 novembre 1987
( # 87002587 )
Main Street
41 ° 38′56 ″ N 70 ° 20′53 ″ O  /  41.648889 ° N 70.348056 ° O  / 41.648889; -70.348056  ( Quartiere storico di Centreville )
Barnstable
22 Casa Lemuel B. Chase
Casa Lemuel B. Chase
13 marzo 1987
( # 87000267 )
340 Scudder Ave.
41 ° 38′21 ″ N 70 ° 18′14 ″ O  /  41.639167 ° N 70.303889 ° O  / 41.639167; -70.303889  (Casa Lemuel B. Chase )
Barnstable
23 Col. Charles Codman Estate
Col. Charles Codman Estate
13 marzo 1987
( # 87000321 )
Bluff Point Dr.
41 ° 36′41 ″ N 70 ° 25′58 ″ O  /  41.6114 ° N 70.4328 ° O  / 41.6114; -70.4328  ( Col. Charles Codman Estate )
Barnstable
24 Distretto storico di Cotuit
Distretto storico di Cotuit
10 novembre 1987
( # 87000317 )
Main St., Lowell e Ocean View Aves. delimitato da Osterville Harbour, Nantucket Sound e Popponessett Bay
41 ° 36′57 ″ N 70 ° 26′14 ″ O  /  41.615833 ° N 70.437222 ° O  / 41.615833; -70.437222  ( Distretto storico di Cotuit )
Barnstable
25 Distretto storico di Craigville
Distretto storico di Craigville
10 novembre 1987
( # 87000275 )
Porto di Centerville, Nantucket Sound , Red Lily Pond e Lake Elizabeth
41 ° 38′29 ″ N 70 ° 19′58 ″ O  /  41.641389 ° N 70.332778 ° O  / 41.641389; -70.332778  ( Distretto storico di Craigville )
Barnstable
26 Benomi e Barnabas Crocker House
Benomi e Barnabas Crocker House
13 marzo 1987
( # 87000216 )
325 Willow St.
41 ° 42′18 ″ N 70 ° 23′10 ″ O  /  41.705 ° N 70.386111 ° O  / 41.705; -70.386111  ( Benomi e Barnabas Crocker House )
Barnstable
27 Capt. Alexander Crocker House
Capt. Alexander Crocker House
13 marzo 1987
( # 87000274 )
358 Sea St.
41 ° 38′20 ″ N 70 ° 17′27 ″ O  /  41.638889 ° N 70.290833 ° O  / 41.638889; -70.290833  ( Capt. Alexander Crocker House )
Barnstable
28 Ebenezer Crocker Jr. House
Ebenezer Crocker Jr. House
10 novembre 1987
( # 87000323 )
49 Putnam Ave.
41 ° 37′17 ″ N 70 ° 26′03 ″ O  /  41.621389 ° N 70.434167 ° O  / 41.621389; -70.434167  ( Ebenezer Crocker Jr. House )
Barnstable
29 Lot Crocker House
Lot Crocker House
13 marzo 1987
( # 87000263 )
284 Gosnold St.
41 ° 38′19 ″ N 70 ° 17′27 ″ O  /  41.638611 ° N 70.290833 ° O  / 41.638611; -70.290833  ( Lot Crocker House )
Barnstable
30 Daniel Crosby House
Daniel Crosby House
18 settembre 1987
( # 87000306 )
18 Bay St.
41 ° 37′44 ″ N 70 ° 23′18 ″ O  /  41.628889 ° N 70.388333 ° O  / 41.628889; -70.388333  ( Casa di Daniel Crosby )
Barnstable
31 Casa Crowell-Smith
Casa Crowell-Smith
13 marzo 1987
( # 87000272 )
33 Pine St.
41 ° 38′57 ″ N 70 ° 17′19 ″ O  /  41.649167 ° N 70.288611 ° O  / 41.649167; -70.288611  (Casa Crowell-Smith )
Barnstable
32 Fuller House
Fuller House
13 marzo 1987
( # 87000325 )
Parker Rd.
41 ° 41′42 "N 70 ° 22′01" O  /  41.695 ° N 70.366944 ° O  / 41.695; -70.366944  ( Fuller House )
Barnstable
33 Gifford Farm
Gifford Farm
13 marzo 1987
( # 87000245 )
261 Cotuit Rd.
41 ° 39′26 "N 70 ° 24′43" O  /  41.657222 ° N 70.411944 ° O  / 41.657222; -70.411944  ( Fattoria di Gifford )
Barnstable
34 Il dottor Edward Francis Gleason House
Il dottor Edward Francis Gleason House
18 settembre 1987
( # 87000262 )
88 Lewis Bay Rd.
41 ° 39′10 "N 70 ° 16′30" O  /  41.652778 ° N 70.275 ° O  / 41.652778; -70.275  (Casa del dottor Edward Francis Gleason )
Barnstable
35 Goodspeed House
Goodspeed House
13 marzo 1987
( # 87000235 )
271 River Rd.
41 ° 39′32 "N 70 ° 25′10" O  /  41.658889 ° N 70.419444 ° O  / 41.658889; -70.419444  ( Casa Goodspeed )
Barnstable
36 Capt. Thomas Gray House
Capt. Thomas Gray House
13 marzo 1987
( # 87000280 )
Strada principale 14
41 ° 39′25 ″ N 70 ° 16′20 ″ O  /  41.656944 ° N 70.272222 ° O  / 41.656944; -70.272222  ( Capt. Thomas Gray House )
Barnstable
37 Capt. William Hallett House
Capt. William Hallett House
18 settembre 1987
( # 87000296 )
570 Main Street
41 ° 38′59 ″ N 70 ° 17′24 ″ O  /  41.649722 ° N 70.29 ° O  / 41.649722; -70.29  ( Capt. William Hallett House )
Barnstable
38 Casa di Seth Hallett
Casa di Seth Hallett
18 settembre 1987
( # 87000298 )
110 Main Street
41 ° 39′22 ″ N 70 ° 16′32 ″ O  /  41.656111 ° N 70.275556 ° O  / 41.656111; -70.275556  ( Casa di Seth Hallett )
Barnstable
39 Harlow Homestead
Harlow Homestead
18 settembre 1987
( # 87000324 )
391 Main St.
41 ° 37′42 ″ N 70 ° 26′35 ″ O  /  41.628333 ° N 70.443056 ° O  / 41.628333; -70.443056  ( Harlow Homestead )
Barnstable
40 Gideon Hawley House
Gideon Hawley House
13 marzo 1987
( # 87000312 )
4766 Falmouth Rd.
41 ° 38′11 "N 70 ° 27′16" O  /  41.636389 ° N 70.454444 ° O  / 41.636389; -70.454444  ( Gideon Hawley House )
Barnstable
41 Hinckley Homestead
Hinckley Homestead
18 settembre 1987
( # 87000248 )
1740 S. County Rd.
41 ° 38′57 "N 70 ° 23′52" O  /  41.649167 ° N 70.397778 ° O  / 41.649167; -70.397778  ( Hinckley Homestead )
Barnstable
42 Capt. Joseph Hinckley House
Capt. Joseph Hinckley House
13 marzo 1987
( # 87000249 )
142 Old Stage Rd.
41 ° 39′14 "N 70 ° 21′02" O  /  41.653889 ° N 70.350556 ° O  / 41.653889; -70.350556  ( Capt. Joseph Hinckley House )
Barnstable
43 Nymphus Hinckley House
Nymphus Hinckley House
13 marzo 1987
( # 87000250 )
38 Bay St.
41 ° 37′44 ″ N 70 ° 23′18 ″ O  /  41.628889 ° N 70.388333 ° O  / 41.628889; -70.388333  ( Casa di Nymphus Hinckley )
Barnstable
44 Casa di S. Alexander Hinckley
Casa di S. Alexander Hinckley
18 settembre 1987
( # 87000279 )
151 Pine St.
41 ° 38′48 ″ N 70 ° 17′13 ″ O  /  41.646667 ° N 70.286944 ° O  / 41.646667; -70.286944  (Casa di S. Alexander Hinckley )
Barnstable
45 Quartiere storico del porto di Hyannis
Quartiere storico del porto di Hyannis
10 novembre 1987
( # 87000259 )
Delimitata approssimativamente da Massachusetts Ave. ed Edgehill Rd., Hyannis Ave., Hyannis Harbour e Scudder Ave.
41 ° 37′52 ″ N 70 ° 17′55 ″ O  /  41.631111 ° N 70.298611 ° O  / 41.631111; -70.298611  ( Quartiere storico del porto di Hyannis )
Barnstable
46 Quartiere storico di Hyannis Road
Quartiere storico di Hyannis Road
13 marzo 1987
( # 87000231 )
Delimitata da Old King's Highway, Bow Ln., Binari ferroviari Cape Cod Branch e Hyannis Road.
41 ° 41′23 "N 70 ° 18′04" O  /  41.689722 ° N 70.301111 ° O  / 41.689722; -70.301111  ( Quartiere storico di Hyannis Road )
Barnstable
47 Herman Isham House
Herman Isham House
13 marzo 1987
( # 87000295 )
1322 Main Street
41 ° 38′27 ″ N 70 ° 23′34 ″ O  /  41.640833 ° N 70.392778 ° O  / 41.640833; -70.392778  ( Casa di Herman Isham )
Barnstable
48 John Jenkins Homestead
John Jenkins Homestead
13 marzo 1987
( # 87000318 )
Chiesa St.
41 ° 41′41 ″ N 70 ° 22′12 ″ W  /  41.694722 ° N 70.37 ° O  / 41.694722; -70.37  ( John Jenkins Homestead )
Barnstable
49 Casa di Joseph Jenkins
Casa di Joseph Jenkins
13 marzo 1987
( # 87000322 )
310 Pine St.
41 ° 41′29 ″ N 70 ° 22′15 ″ W  /  41.691389 ° N 70.370833 ° O  / 41.691389; -70.370833  ( Casa di Joseph Jenkins )
Barnstable
50 Fattoria Jenkins-Whelden
Fattoria Jenkins-Whelden
13 marzo 1987
( # 87000320 )
221 Pine St.
41 ° 41′30 ″ N 70 ° 22′29 ″ W  /  41.691667 ° N 70.374722 ° O  / 41.691667; -70.374722  ( Fattoria Jenkins-Whelden )
Barnstable
51 Kennedy Compound
Kennedy Compound
28 novembre 1972
( # 72001302 )
Irving e Marchant Aves.
41 ° 37′49 "N 70 ° 18′12" O  /  41.630278 ° N 70.303333 ° O  / 41.630278; -70.303333  ( Kennedy Compound )
Porto di Hyannis Dimore storiche della famiglia Kennedy
52 Liberty Hall
Liberty Hall
13 marzo 1987
( # 87000246 )
Main Street
41 ° 39′15 ″ N 70 ° 24′46 ″ O  /  41.654167 ° N 70.412778 ° O  / 41.654167; -70.412778  ( Sala della Libertà )
Barnstable
53 Lincoln House Club
Lincoln House Club
13 marzo 1987
( # 87000301 )
135 Bridge St.
41 ° 37′19 ″ N 70 ° 23′47 ″ W  /  41.621944 ° N 70.396389 ° O  / 41.621944; -70.396389  ( Lincoln House Club )
Barnstable
54 Capt. George Lovell House
Capt. George Lovell House
10 novembre 1987
( # 87000290 )
8 E. Bay Rd.
41 ° 37′40 "N 70 ° 22′46" O  /  41.627778 ° N 70.379444 ° O  / 41.627778; -70.379444  ( Capt. George Lovell House )
Barnstable
55 Nehemiah Lovell House
Nehemiah Lovell House
18 settembre 1987
( # 87000291 )
691 Main Street
41 ° 37′38 ″ N 70 ° 22′51 ″ O  /  41.627222 ° N 70.380833 ° O  / 41.627222; -70.380833  ( Casa di Nehemiah Lovell )
Barnstable
56 William Marston House
William Marston House
13 marzo 1987
( # 87000234 )
71 Cotuit Rd.
41 ° 39′08 "N 70 ° 24′53" O  /  41.652222 ° N 70.414722 ° O  / 41.652222; -70.414722  ( William Marston House )
Barnstable
57 Marstons Mills Hearse House and Cemetery
Marstons Mills Hearse House and Cemetery
13 marzo 1987
( # 87000302 )
MA 149
41 ° 39′43 "N 70 ° 24′31" O  /  41.661944 ° N 70.408611 ° O  / 41.661944; -70.408611  ( Casa e cimitero di Marstons Mills Hearse )
Barnstable
58 Merrill Estate
Merrill Estate
18 settembre 1987
( # 87000268 )
1874 S. County Rd.
41 ° 39′06 "N 70 ° 24′11" O  /  41.651667 ° N 70.403056 ° O  / 41.651667; -70.403056  ( Merrill Estate )
Barnstable
59 Chiesa metodista
Chiesa metodista
13 marzo 1987
( # 87000247 )
2135 Main Street
41 ° 39′14 ″ N 70 ° 24′43 ″ O  /  41.653889 ° N 70.411944 ° O  / 41.653889; -70.411944  ( Chiesa metodista )
Barnstable Ora la Marstons Mills Community Church
60 Mill Way Historic District
Mill Way Historic District
10 novembre 1987
( # 87000271 )
Mill Way Rd.
41 ° 42′12 "N 70 ° 18′01" O  /  41.703333 ° N 70.300278 ° O  / 41.703333; -70.300278  ( Distretto storico di Mill Way )
Barnstable
61 Distretto storico del gruppo municipale
Distretto storico del gruppo municipale
10 novembre 1987
( # 87000288 )
Delimitata approssimativamente da Main, Municipal Buildings, South e Pearl Sts.
41 ° 39′06 "N 70 ° 17′02" O  /  41.651667 ° N 70.283889 ° O  / 41.651667; -70.283889  ( Distretto storico del gruppo municipale )
Barnstable
62 Vecchia prigione
Vecchia prigione
2 luglio 1971
( # 71000078 )
US Route 6 A
41 ° 42′00 ″ N 70 ° 17′56 ″ O  /  41,7 ° N 70,298889 ° O  / 41,7; -70.298889  ( Vecchia prigione )
Barnstable
63 Old King's Highway Historic District
Old King's Highway Historic District
12 marzo 1987
( # 87000314 )
Old King's Highway tra la linea della città di Sandwich a ovest fino alla linea della città di Yarmouth a est
41 ° 42′24 ″ N 70 ° 20′20 ″ O  /  41.706667 ° N 70.338889 ° O  / 41.706667; -70.338889  ( Old King's Highway Historic District )
Barnstable
64 Chiesa battista di Osterville
Chiesa battista di Osterville
18 settembre 1987
( # 87000292 )
Main Street
41 ° 37′41 ″ N 70 ° 23′09 ″ O  /  41.628056 ° N 70.385833 ° O  / 41.628056; -70.385833  ( Chiesa battista di Osterville )
Barnstable
65 William e Jane Phinney House
William e Jane Phinney House
13 marzo 1987
( # 87000284 )
555 Phinney's Ln.
41 ° 39′47 "N 70 ° 19′42" O  /  41.663056 ° N 70.328333 ° O  / 41.663056; -70.328333  ( William e Jane Phinney House )
Barnstable
66 Pleasant-School Street Historic District
Pleasant-School Street Historic District
10 novembre 1987
( # 87000257 )
Delimitata approssimativamente da Main, School, South e Pleasant Sts.
41 ° 39′12 "N 70 ° 16′42" O  /  41.653333 ° N 70.278333 ° O  / 41.653333; -70.278333  ( Quartiere storico di Pleasant-School Street )
Barnstable
67 Nelson Rhodehouse House
Nelson Rhodehouse House
13 marzo 1987
( # 87000308 )
131 Main St.
41 ° 38′02 ″ N 70 ° 26′59 ″ O  /  41.633889 ° N 70.449722 ° O  / 41.633889; -70.449722  ( Nelson Rhodehouse House )
Barnstable
68 John Richardson House
John Richardson House
18 settembre 1987
( # 87000281 )
242 Phinney's Ln.
41 ° 39′28 "N 70 ° 20′21" O  /  41.657778 ° N 70.339167 ° O  / 41.657778; -70.339167  ( Casa di John Richardson )
Barnstable
69 Casa di Joseph Robbins
Casa di Joseph Robbins
10 novembre 1987
( # 87000289 )
12 Bay St.
41 ° 37′44 ″ N 70 ° 23′18 ″ O  /  41.628889 ° N 70.388333 ° O  / 41.628889; -70.388333  ( Casa di Joseph Robbins )
Barnstable
70 Round House
Round House
13 marzo 1987
( # 87000282 )
971 W. Main Street
41 ° 39′23 ″ N 70 ° 19′46 ″ O  /  41.656389 ° N 70.329444 ° O  / 41.656389; -70.329444  ( Casa rotonda )
Barnstable
71 La follia di Sampson-Josiah Sampson House
La follia di Sampson-Josiah Sampson House
18 settembre 1987
( # 87000326 )
40 Old King's Rd.
41 ° 37′49 "N 70 ° 26′53" O  /  41.630278 ° N 70.448056 ° O  / 41.630278; -70.448056  ( Sampson's Folly-Josiah Sampson House )
Barnstable
72 Distretto delle risorse culturali di Sandy Neck
Distretto delle risorse culturali di Sandy Neck
10 novembre 1987
( # 87000305 )
Penisola di Sandy Neck
41 ° 43′57 ″ N 70 ° 20′25 ″ O  /  41.732636 ° N 70.340366 ° O  / 41.732636; -70.340366  ( Distretto delle risorse culturali di Sandy Neck )
Barnstable
73 Quartiere storico di Santuit
Quartiere storico di Santuit
10 novembre 1987
( # 87000319 )
MA 28
41 ° 38′16 "N 70 ° 27′04" O  /  41.637778 ° N 70.451111 ° O  / 41.637778; -70.451111  ( Quartiere storico di Santuit )
Barnstable
74 Ufficio postale Santuit
Ufficio postale Santuit
10 novembre 1987
( # 87000309 )
Strada principale
41 ° 38′06 ″ N 70 ° 27′01 ″ O  /  41.635 ° N 70.450278 ° O  / 41.635; -70.450278  ( Ufficio postale Santuit )
Barnstable
75 Casa di Matthias Smith
Casa di Matthias Smith
13 marzo 1987
( # 87000240 )
375 Cedar St.
41 ° 42′23 ″ N 70 ° 23′36 ″ O  /  41.706389 ° N 70.393333 ° O  / 41.706389; -70.393333  ( Casa di Matthias Smith )
Barnstable
76 Indicatore di confine della città
Indicatore di confine della città
18 settembre 1987
( # 87000269 )
Gara Ln. A Sandwich town line
41 ° 41′11 ″ N 70 ° 26′12 ″ W  /  41.686389 ° N 70.436667 ° O  / 41.686389; -70.436667  ( Indicatore di confine della città )
Barnstable
77 Indicatore di confine della linea cittadina
Indicatore di confine della linea cittadina
18 settembre 1987
( # 87000242 )
Great Hill Rd.
41 ° 43′19 "N 70 ° 24′04" O  /  41.721944 ° N 70.401111 ° O  / 41.721944; -70.401111  ( Indicatore di confine della linea cittadina )
Barnstable
78 Indicatore di confine della linea cittadina
Indicatore di confine della linea cittadina
18 settembre 1987
( # 87000243 )
410 High St.
41 ° 43′19 ″ N 70 ° 24′04 ″ O  /  41.721944 ° N 70.401111 ° O  / 41.721944; -70.401111  ( Indicatore di confine della linea cittadina )
Barnstable
79 Customshouse degli Stati Uniti
Customshouse degli Stati Uniti
12 novembre 1975
( # 75000239 )
Cobbs Hill, MA 6A
41 ° 42′01 ″ N 70 ° 17′57 ″ O  /  41.700278 ° N 70.299167 ° O  / 41.700278; -70.299167  ( US Customshouse )
Barnstable
80 Barzillai Weeks House
Barzillai Weeks House
13 marzo 1987
( # 87000241 )
313 High St.
41 ° 43′15 ″ N 70 ° 23′59 ″ O  /  41.720833 ° N 70.399722 ° O  / 41.720833; -70.399722  ( Barzillai Weeks House )
Barnstable
81 Distretto storico di West Barnstable Village-Meetinghouse Way
Distretto storico di West Barnstable Village-Meetinghouse Way
10 novembre 1987
( # 87000255 )
Meetinghouse Way da County Rd. alla casa di riunione
41 ° 42′10 ″ N 70 ° 22′45 ″ O  /  41.702778 ° N 70.379167 ° O  / 41.702778; -70.379167  ( Distretto storico di West Barnstable Village-Meetinghouse Way )
Barnstable
82 Josiah B. Whitman House
Josiah B. Whitman House
13 marzo 1987
( # 87000236 )
210 Maple St.
41 ° 42′31 ″ N 70 ° 23′21 ″ O  /  41.708611 ° N 70.389167 ° O  / 41.708611; -70.389167  (Casa di Josiah B. Whitman )
Barnstable
83 Wianno Club
Wianno Club
2 marzo 1979
( # 79000325 )
Seaview Ave.
41 ° 36′58 ″ N 70 ° 22′17 ″ O  /  41.616111 ° N 70.371389 ° O  / 41.616111; -70.371389  ( Wianno Club )
Osterville
84 Distretto storico di Wianno
Distretto storico di Wianno
10 novembre 1987
( # 87000316 )
Circa E. Bay Rd., Wianno e Sea View Aves. tra Nantucket Sound e Crystal Lake
41 ° 37′03 ″ N 70 ° 22′24 ″ O  /  41.6175 ° N 70.373333 ° O  / 41.6175; -70.373333  ( Distretto storico di Wianno )
Barnstable
85 Distretto storico di Yarmouth Camp Ground
Distretto storico di Yarmouth Camp Ground
28 agosto 1990
( # 90001244 )
A sud della Mid-Cape Highway ( US Route 6 ) e approssimativamente delimitata da County Ave., Willow St., Wood Rd. E Camp Ground Pond
41 ° 40′59 ″ N 70 ° 15′44 ″ O  /  41.683056 ° N 70.262222 ° O  / 41.683056; -70.262222  ( Distretto storico di Yarmouth Camp Ground )
Barnstable e Yarmouth

Precedenti elenchi

Nome sul registro Immagine Data elencata Data rimossa Posizione Città o paese Descrizione
1 Barnstable Fair Hall
Barnstable Fair Hall
7 marzo 1979
(# 80000436)
12 giugno 1980 3512 Main St.
Barnstable Demolito

Guarda anche

Riferimenti